Cargando...

Datos de HEBEL MANAGEMENT SL

HEBEL MANAGEMENT SL

Objeto social

LA ADQUISICION, CESION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION, GESTION Y NEGOCIACION EN GENERAL, POR Y A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DE TITULOS, VALORES, ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES, PATENTES, ETC.
CNAE 6420 - Actividades de las sociedades holding

CIF

B83146688

Fecha constitución

13/11/2001

Duración

21 años
(Extinguida el 30/03/2023)

Capital social

70.000,00 €

Ventas

0.5M €

Registro

Madrid

Últimas cuentas depositadas

2021

Órgano administración

Administradores mancomunados



Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de HEBEL MANAGEMENT SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.


Ejercicio
Disponibilidad
2019
3 horas
2020
3 horas
2021
3 horas
Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

EntidadRelaciónEntidad/RelaciónDesdeHasta
Garcia Casado Maria Liquidador Garcia Casado Maria
Liquidador
30/03/202330/03/2023
Garcia Odriozola Miguel Angel Represent. Garcia Odriozola Miguel Angel
Represent.
15/12/202130/03/2023
Garcia Razon Agustin Represent. Garcia Razon Agustin
Represent.
15/12/202130/03/2023
HERGAROVAL SL Adm. Mancom. HERGAROVAL SL
Adm. Mancom.
15/12/202130/03/2023
SEQUENCE CHAIN SL Adm. Mancom. SEQUENCE CHAIN SL
Adm. Mancom.
15/12/202130/03/2023
Garcia Odriozola Miguel Angel Apod. Garcia Odriozola Miguel Angel
Apod.
22/03/201230/03/2023
SEQUENCE CHAIN SL Apod. SEQUENCE CHAIN SL
Apod.
22/03/201230/03/2023
FIRADEX SL Apod. FIRADEX SL
Apod.
22/03/201230/03/2023
Garcia Razon Agustin Represent.143 RRM Garcia Razon Agustin
Represent.143 RRM
24/02/201230/03/2023
Garcia Carroggio Antonio Represent.143 RRM Garcia Carroggio Antonio
Represent.143 RRM
24/02/201230/03/2023
Garcia Odriozola Jose Manuel Apod. Garcia Odriozola Jose Manuel
Apod.
30/03/2023
Lambarri Martin Jose Apod. Lambarri Martin Jose
Apod.
30/03/2023
Garcia Uriarte Idoia Apod. Garcia Uriarte Idoia
Apod.
30/03/2023
Lambarri Martin Jose Apod. Lambarri Martin Jose
Apod.
30/03/2023
SEQUENCE CHAIN SL Consej. SEQUENCE CHAIN SL
Consej.
24/02/201215/12/2021
FIRADEX SL Consej. FIRADEX SL
Consej.
24/02/201215/12/2021
FIRADEX SL Secr. FIRADEX SL
Secr.
24/02/201215/12/2021
Garcia Odriozola Miguel Angel Presid. Garcia Odriozola Miguel Angel
Presid.
24/02/201215/12/2021
Garcia Odriozola Miguel Angel Consej. Garcia Odriozola Miguel Angel
Consej.
15/12/2021
Garcia Odriozola Francisco Javier Consej. Garcia Odriozola Francisco Javier
Consej.
15/12/2021
Garcia Odriozola Francisco Javier Apod. Garcia Odriozola Francisco Javier
Apod.
22/03/2012
Garcia-razon Garcia Agustin Apod. Garcia-razon Garcia Agustin
Apod.
22/03/2012
Garcia Odriozola Miguel Angel Secr. Garcia Odriozola Miguel Angel
Secr.
24/02/2012
Garcia Razon Agustin Consej. Garcia Razon Agustin
Consej.
24/02/2012
Garcia Munte Garcia Javier Consej. Garcia Munte Garcia Javier
Consej.
24/02/2012
Garcia Carroggio Antonio Consej. Garcia Carroggio Antonio
Consej.
24/02/2012
Garcia Uriarte Idoia Consej. Garcia Uriarte Idoia
Consej.
24/02/2012
Garcia Odriozola Francisco Javier Presid. Garcia Odriozola Francisco Javier
Presid.
24/02/2012
Garcia Razon Agustin Vicepres. Garcia Razon Agustin
Vicepres.
24/02/2012

Vinculaciones

Vinculaciones societarias de HEBEL MANAGEMENT SLAARUS INTERCONTINENTAL SLAARUS INTERCONTINENTAL SLGARONAFOL SLGARONAFOL SLAARUS MARITIMA SAAARUS MARITIMA SAAARUS SLAARUS SLPLURITRADING SLPLURITRADING SLGARCIA RAZON TRADING SLGARCIA RAZON TRADING SLSILORDAL SLSILORDAL SLTRISTAR ADVISORY SERVICES  SLTRISTAR ADVISORY SERVICES  SLPREMIERE OIL SLPREMIERE OIL SLDORGASIL SLDORGASIL SLMANUEL GARCIA MENDOZA SAMANUEL GARCIA MENDOZA SAFIRADEX SLFIRADEX SLESNEIPOL SLESNEIPOL SLHEBEL MANAGEMENT SLHEBEL MANAGEMENT SLWEST AGENT SERVICES SLWEST AGENT SERVICES SLRECYOIL ENERGY SLRECYOIL ENERGY SLAVITUS GESTION Y ADMINISTRACION SLAVITUS GESTION Y ADMINISTRACION SLNICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLNICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLTALENTO'S ADVISORY SERVICES SLTALENTO'S ADVISORY SERVICES SLGarcia Carroggio AntonioGarcia Carroggio AntonioGarcia Razon AgustinGarcia Razon AgustinGarcia Odriozola Miguel AngelGarcia Odriozola Miguel AngelGarcia Odriozola Francisco JavierGarcia Odriozola Francisco JavierALTAIR GESTION GLOBAL  SLALTAIR GESTION GLOBAL  SLFIRADEX SL, Consejero Delegado,Consejero,Secretario de AARUS INTERCONTINENTAL SLGarcia Razon Agustin, Administrador Único de GARONAFOL SLGarcia Carroggio Antonio, Presidente,Consejero de AARUS MARITIMA SAGarcia Razon Agustin, Consejero de AARUS MARITIMA SAGarcia Razon Agustin, Administrador Único de AARUS SLFIRADEX SL, Administrador Solidario de PLURITRADING SLESNEIPOL SL, Administrador Solidario de PLURITRADING SLGarcia Carroggio Antonio, Representante 143 RRM de PLURITRADING SLGarcia Razon Agustin, Representante 143 RRM de PLURITRADING SLGarcia Razon Agustin, Administrador Único de GARCIA RAZON TRADING SLFIRADEX SL, Administrador Solidario de SILORDAL SLGarcia Carroggio Antonio, Representante 143 RRM de SILORDAL SLGarcia Razon Agustin, Representante 143 RRM de SILORDAL SLGARCIA RAZON TRADING SL, Administrador Solidario de TRISTAR ADVISORY SERVICES  SLFIRADEX SL, Administrador Solidario de TRISTAR ADVISORY SERVICES  SLGarcia Carroggio Antonio, Representante 143 RRM de TRISTAR ADVISORY SERVICES  SLGarcia Razon Agustin, Representante 143 RRM de TRISTAR ADVISORY SERVICES  SLGARCIA RAZON TRADING SL, Consejero,Presidente,Consejero Delegado Solidario de PREMIERE OIL SLFIRADEX SL, Secretario,Consejero de PREMIERE OIL SLGarcia Carroggio Antonio, Representante de PREMIERE OIL SLGarcia Razon Agustin, Representante de PREMIERE OIL SLAARUS INTERCONTINENTAL SL, Socio Único de DORGASIL SLGarcia Carroggio Antonio, Consejero,Presidente de DORGASIL SLGarcia Odriozola Miguel Angel, Administrador Mancomunado de MANUEL GARCIA MENDOZA SAGarcia Odriozola Francisco Javier, Administrador Mancomunado de MANUEL GARCIA MENDOZA SAGarcia Carroggio Antonio, Administrador Único de FIRADEX SLGarcia Razon Agustin, Representante 143 RRM de ESNEIPOL SLGARCIA RAZON TRADING SL, Consejero de HEBEL MANAGEMENT SLFIRADEX SL, Secretario,Consejero de HEBEL MANAGEMENT SLGarcia Carroggio Antonio, Representante 143 RRM de HEBEL MANAGEMENT SLGarcia Razon Agustin, Representante 143 RRM de HEBEL MANAGEMENT SLGarcia Odriozola Miguel Angel, Presidente de HEBEL MANAGEMENT SLESNEIPOL SL, Liquidador de WEST AGENT SERVICES SLGarcia Carroggio Antonio, Representante 143 RRM de WEST AGENT SERVICES SLGarcia Odriozola Miguel Angel, Administrador Único de RECYOIL ENERGY SLGarcia Razon Agustin, Administrador Único de AVITUS GESTION Y ADMINISTRACION SLGARCIA RAZON TRADING SL, Consejero de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLFIRADEX SL, Consejero,Secretario de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLHEBEL MANAGEMENT SL, Socio Único de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLGarcia Carroggio Antonio, Representante de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLGarcia Razon Agustin, Representante,Representante 143 RRM de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLGarcia Odriozola Miguel Angel, Consejero,Presidente de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLGarcia Odriozola Francisco Javier, Consejero de NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SLFIRADEX SL, Administrador Solidario de TALENTO'S ADVISORY SERVICES SLESNEIPOL SL, Administrador Solidario de TALENTO'S ADVISORY SERVICES SLGarcia Carroggio Antonio, Representante de TALENTO'S ADVISORY SERVICES SLGarcia Razon Agustin, Representante de TALENTO'S ADVISORY SERVICES SLGarcia Odriozola Miguel Angel, Administrador Mancomunado de ALTAIR GESTION GLOBAL  SLGarcia Odriozola Francisco Javier, Administrador Mancomunado de ALTAIR GESTION GLOBAL  SL

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por HEBEL MANAGEMENT SL o en los que participa indirectamente.

Mostrar Filtros

  • Ceses/Dimisiones.

    Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

    Administradores Mancomunados
    Representantes
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 30/03/2023. Núm. 170116. T 43765, F 40, S 8, H M 290795, I/A 8 

    Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 30/03/2023. Núm. 170116. T 43765, F 40, S 8, H M 290795, I/A 8 

    Nombramientos.

    Con fecha 30 de marzo de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Garcia Casado Maria como Liquidador de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 30/03/2023. Núm. 170116. T 43765, F 40, S 8, H M 290795, I/A 8 

    Disolución.

    Se disuelve la sociedad voluntariamente.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 30/03/2023. Núm. 170116. T 43765, F 40, S 8, H M 290795, I/A 8 

    Extinción.

    El 30 de marzo de 2023 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 30/03/2023. Núm. 170116. T 43765, F 40, S 8, H M 290795, I/A 8 
  • Reducción de capital.

    Con fecha 7 de julio de 2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la reducción de 380.000 € del capital social de la empresa. Esta reducción representa un 84.44 % de reducción del capital, quedando un capital social resultante de 70.000€.

    Capital social anterior:450.000 €
    Reducción de capital:380.000 €
    Capital social resultante:70.000 €
    % reducción:84.44 %
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 07/07/2022. Núm. 330180. T 16992, F 225, S 8, H M 290795, I/A 7 
  • Ceses/Dimisiones.

    Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

    Presidente
    Consejero
    Consejeros
    Secretario
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 15/12/2021. Núm. 551647. T 16992, F 224, S 8, H M 290795, I/A 6 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Administradores Mancomunados
    Representantes
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 15/12/2021. Núm. 551647. T 16992, F 224, S 8, H M 290795, I/A 6 

    Otros conceptos:

    Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 15/12/2021. Núm. 551647. T 16992, F 224, S 8, H M 290795, I/A 6 
  • Cambio de domicilio social.

    Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ UGARTEBEITIA 7 2º - DEPARTAMENTO 7 (BARAKALDO). siendo el nuevo domicilio situado en C/ GARCIA PAREDES 74 - FINCA B, PLANTA 1& (MADRID)..

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 15/10/2013. Núm. 451511. T 16992, F 224, S 8, H M 290795, I/A 5 
  • Declaración de unipersonalidad.

    Publicación de la empresa NICATOR GESTION Y ADMINISTRACION SL: Con fecha 22 de abril de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias la sociedad HEBEL MANAGEMENT SL
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/04/2013. Núm. 202499. T 30973, F 174, S 8, H M 557522, I/A 2 
  • Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/03/2012. Núm. 161202. T 5275, F 170, S 8, H BI 60026, I/A 4 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Apoderados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/03/2012. Núm. 161202. T 5275, F 170, S 8, H BI 60026, I/A 4 

    Nombramientos.

    Con fecha 22 de marzo de 2012 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de FIRADEX SL como Apoderado de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/03/2012. Núm. 161203. T 5275, F 172, S 8, H BI 60026, I/A 5 
  • Cambio de domicilio social.

    Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio C/ UGARTEBEITIA 7 2º - DEPARTAMENTO 7 (BARAKALDO)..

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/03/2012. Núm. 140841. T 5275, F 169, S 8, H BI 60026, I/A 2 

    Ampliación de capital.

    El capital social de la empresa se incrementa en un 1166.67 % (ampliación de 210.000 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 18.000€ de capital social a 228.000€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 14 de marzo de 2012.

    Capital social anterior:18.000 €
    Aumento de capital:210.000 €
    Capital social resultante:228.000 €
    % incremento:1166.67 %
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/03/2012. Núm. 140842. T 5275, F 170, S 8, H BI 60026, I/A 3 

    Ampliación de capital.

    Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 222.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 97.37 %, dejando el capital social de la sociedad en 450.000€.

    Capital social anterior:228.000 €
    Aumento de capital:222.000 €
    Capital social resultante:450.000 €
    % incremento:97.37 %
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/03/2012. Núm. 140842. T 5275, F 170, S 8, H BI 60026, I/A 3 
  • Revocaciones.

    Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:

    Presidente
    Vicepresidente
    Consejeros
    Secretario
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/02/2012. Núm. 109898. T 39683, F 111, S 8, H B 350855, I/A 9 

    Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Presidente
    Consejero
    Secretario
    Representante 143 RRM
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/02/2012. Núm. 109898. T 39683, F 111, S 8, H B 350855, I/A 9 
  • Depósito de cuentas anuales

    En julio del 2011 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2010 .
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/08/2011. Núm. 669132.  
  • Fe de erratas:

    En el BORME no.128/2011 y con referencia 360037 SE PROCEDE A NOMBRAR A DONAGUSTIN GARCIA RAZON COMO VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POROMISION EN DU DIA.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 12/06/2007. Núm. 120530. T 39683, F 106, S 8, H B 350855, I/A 4 
  • Depósito de cuentas anuales

    En julio del 2010 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2009 .
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/08/2010. Núm. 606836.  
  • Depósito de cuentas anuales

    En julio del 2009 se presentan en el registro las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008 .
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/08/2009. Núm. 456279.  

Informes comerciales Axesor

Informe de CréditoInforme Mercantil, Incidencias y VinculacionesPerfil Comercial de Empresa
Capital social actual y evoluciónIncluye Capital social actual y evoluciónIncluye Capital social actual y evoluciónIncluye Capital social actual y evolución
Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercial
Básica
Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentes
Solo administradores
Incluye Administradores y dirigentes
Solo dirigentes
Empresas relacionadas
(accionistas, participadas,…)
Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Incidencias judiciales y procedimientos concursalesIncluye Incidencias judiciales y procedimientos concursalesIncluye Incidencias judiciales y procedimientos concursalesIncluye Incidencias judiciales y procedimientos concursales
Impagos en el fichero RAIIncluye Impagos en el fichero RAIIncluye Impagos en el fichero RAIIncluye Impagos en el fichero RAI
Impagos en el fichero Asnef EmpresasIncluye Impagos en el fichero Asnef EmpresasIncluye Impagos en el fichero Asnef EmpresasIncluye Impagos en el fichero Asnef Empresas
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Extracto del balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Extracto del balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financieras
AccederAccederAcceder

HEBEL MANAGEMENT SL fué una empresa constituida el 13/11/2001 y extinguida el 30/03/2023 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas era Actividades de las sociedades holding.

capital social de la empresa es de 70.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.

HEBEL MANAGEMENT SL tiene 4 cargos directivos en activo y 9 cargos directivos históricos.